-
CROMWELL SERVICE STATION LIMITED - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05509537
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Office D Beresford House
- Town Quay
- Southampton
- SO14 2AQ Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ UK
Management
- Geschäftsführung
- BARRETT, Joseph James
- DIVINEY, John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.07.2005
- Gelöscht am:
- 2022-12-27
- SIC/NACE
- 47300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Petrogas Group Uk Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- WILCHAP 399 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-26
- Letzte Einreichung: 2019-07-15
-
CROMWELL SERVICE STATION LIMITED Firmenbeschreibung
- CROMWELL SERVICE STATION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05509537. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.07.2005 registriert. CROMWELL SERVICE STATION LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WILCHAP 399 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47300" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Office D Beresford House erreicht werden.
Jetzt sichern CROMWELL SERVICE STATION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cromwell Service Station Limited - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CROMWELL SERVICE STATION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
second-filing-of-secretary-termination-with-name (2021-09-09) - RP04TM02
-
second-filing-withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2021-09-09) - RP04PSC09
-
second-filing-notification-of-a-person-with-significant-control (2021-09-09) - RP04PSC02
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2021-09-09) - RP04CS01
-
second-filing-of-director-termination-with-name (2021-09-10) - RP04TM01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2021-09-09) - RP04AP01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-03-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-01-31) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-01-31) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-01-31) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-26) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-10-10) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-09) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-10-09) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-15) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-28) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-03) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-15) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-11-15) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-21) - AD01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-11-22) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-22) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-03) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-21) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-25) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-08-23) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-10-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-10-15) - AA
-
legacy (2009-08-05) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-13) - 288c
-
legacy (2008-08-06) - 363a
-
legacy (2008-07-25) - 288c
-
legacy (2008-06-24) - 225
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-23) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-04-19) - AA
-
legacy (2007-07-23) - 363a
-
legacy (2007-12-21) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-09-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-03) - 287
-
legacy (2005-12-07) - 395
-
legacy (2005-11-25) - 395
-
legacy (2005-11-16) - 88(2)R
-
legacy (2005-11-07) - 287
-
legacy (2005-11-07) - 288b
-
legacy (2005-11-07) - 288a
-
certificate-change-of-name-company (2005-09-30) - CERTNM
-
incorporation-company (2005-07-15) - NEWINC