-
ORCHID 11 LIMITED - The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05501145
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Chancery
- 58 Spring Gardens
- Manchester
- M2 1EW The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW UK
Management
- Geschäftsführung
- HARTLEY, Steven Michael
- WORTLEY, Steven Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.07.2005
- Gelöscht am:
- 2020-02-11
- SIC/NACE
- 69201
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- OUTSAUCE CONTRACTOR ACCOUNTING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2016-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-06
-
ORCHID 11 LIMITED Firmenbeschreibung
- ORCHID 11 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05501145. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.07.2005 registriert. ORCHID 11 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen OUTSAUCE CONTRACTOR ACCOUNTING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69201" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.07.2012.Die Firma kann schriftlich über The Chancery erreicht werden.
Jetzt sichern ORCHID 11 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Orchid 11 Limited - The Chancery, 58 Spring Gardens, Manchester, M2 1EW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ORCHID 11 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-02-11) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-07-11) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2019-11-11) - LIQ14
-
resolution (2019-11-11) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-08) - TM02
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-09-12) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-07-20) - 600
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-10) - MR04
-
resolution (2017-05-04) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-01-14) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-01-14) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-01-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-04) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-12) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-12) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-08-12) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-08-12) - AP03
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-01-22) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-11) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-11-20) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-11-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-12-24) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-08-16) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-06-27) - TM01
-
miscellaneous (2013-01-04) - MISC
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-10-26) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-06-01) - AA
-
legacy (2012-06-01) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-25) - AP01
-
legacy (2012-01-19) - MG01
-
legacy (2012-11-06) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-04-06) - AA
-
legacy (2011-12-24) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-07) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-07-07) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-06-01) - AA
-
termination-director-company-with-name (2010-03-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-05-18) - AA
-
legacy (2009-08-14) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-07) - 363a
-
legacy (2008-07-04) - 288b
-
legacy (2008-05-29) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-small (2008-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-25) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-small (2007-09-17) - AA
-
legacy (2007-07-11) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-small (2006-11-05) - AA
-
legacy (2006-07-13) - 225
-
legacy (2006-07-10) - 363a
-
legacy (2006-07-10) - 190
-
legacy (2006-07-10) - 353
-
legacy (2006-07-10) - 287
keyboard_arrow_right 2005
-
incorporation-company (2005-07-06) - NEWINC