-
ROOFING SOUTH WEST LTD - BLACKWELL BATE ACCOUNTANTS, Brunel Court, 122 Fore Street, Saltash, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05500696
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- BLACKWELL BATE ACCOUNTANTS
- Brunel Court
- 122 Fore Street
- Saltash
- Cornwall
- PL12 6JW BLACKWELL BATE ACCOUNTANTS, Brunel Court, 122 Fore Street, Saltash, Cornwall, PL12 6JW UK
Management
- Geschäftsführung
- WESTLAKE, Christine Mary
- WESTLAKE, Kenneth
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.07.2005
- Alter der Firma 2005-07-06 18 Jahre
- SIC/NACE
- 42990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kenneth Westlake
- Mr Kenneth Westlake
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- WASTE DIRECT LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-20
- Letzte Einreichung: 2020-07-06
-
ROOFING SOUTH WEST LTD Firmenbeschreibung
- ROOFING SOUTH WEST LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05500696. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.07.2005 registriert. ROOFING SOUTH WEST LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WASTE DIRECT LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "42990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Blackwell Bate Accountants erreicht werden.
Jetzt sichern ROOFING SOUTH WEST LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Roofing South West Ltd - BLACKWELL BATE ACCOUNTANTS, Brunel Court, 122 Fore Street, Saltash, Grossbritannien
- 2005-07-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ROOFING SOUTH WEST LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-17) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-04) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-20) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-24) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-12-14) - PSC09
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-19) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-18) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-29) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-15) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-08) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-07-08) - CH03
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2009-12-16) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-05-20) - AA
-
legacy (2009-05-14) - 123
-
legacy (2009-05-13) - 225
-
legacy (2009-05-13) - 288a
-
legacy (2009-05-13) - 288b
-
certificate-change-of-name-company (2009-05-06) - CERTNM
-
legacy (2009-08-24) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-05-07) - AA
-
legacy (2008-05-07) - 287
-
legacy (2008-08-20) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-08-20) - AA
-
legacy (2008-05-07) - 288c
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-04-27) - 288b
-
legacy (2007-03-21) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2007-04-27) - AA
-
legacy (2007-08-08) - 363a
-
legacy (2007-06-12) - 288c
-
legacy (2007-06-15) - 287
-
legacy (2007-04-27) - 288a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-09-13) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-09-02) - 288a
-
legacy (2005-07-07) - 288b
-
incorporation-company (2005-07-06) - NEWINC