-
AXIS VENTURA LIMITED - BELL ADVISORY LLP, Tenth Floor 3 Hardman Street, Spinningfields, Manchester, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05493553
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- BELL ADVISORY LLP
- Tenth Floor 3 Hardman Street
- Spinningfields
- Manchester
- M3 3HF BELL ADVISORY LLP, Tenth Floor 3 Hardman Street, Spinningfields, Manchester, M3 3HF UK
Management
- Geschäftsführung
- EVE, Timothy Clive
- WALTON, Michael Desmond
- WILLIAMS, Mark Price
- Prokuristen
- EVE, Timothy Clive
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.06.2005
- Gelöscht am:
- 2021-10-29
- SIC/NACE
- 7487
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2011-07-31
- Letzte Einreichung: 2009-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2010-06-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-07-12
- Letzte Einreichung:
-
AXIS VENTURA LIMITED Firmenbeschreibung
- AXIS VENTURA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05493553. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 28.06.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "7487" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2009 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.06.2010.Die Firma kann schriftlich über Bell Advisory Llp erreicht werden.
Jetzt sichern AXIS VENTURA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Axis Ventura Limited - BELL ADVISORY LLP, Tenth Floor 3 Hardman Street, Spinningfields, Manchester, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AXIS VENTURA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-07-29) - LIQ14
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-10-29) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-02-02) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-02-28) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-02-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-02-22) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-02-25) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-05-29) - 4.20
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-02-18) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2014-02-19) - 4.68
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2013-02-15) - 4.68
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2012-02-02) - 4.68
keyboard_arrow_right 2011
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2011-01-06) - 4.70
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2011-01-06) - 600
-
resolution (2011-01-06) - RESOLUTIONS
-
liquidation-resolution-miscellaneous (2011-01-06) - LIQ MISC RES
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-01-07) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2011-03-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-02) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-02) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-07-02) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-01-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-02) - 190
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-10-01) - AA
-
legacy (2009-07-02) - 363a
-
legacy (2009-07-02) - 353
-
legacy (2009-07-02) - 287
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-09-01) - AA
-
legacy (2008-07-16) - 363a
-
legacy (2008-04-30) - 288a
-
legacy (2008-04-21) - 288b
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-07) - 288c
-
legacy (2007-07-16) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-06-26) - AA
-
legacy (2007-04-26) - 288a
-
legacy (2007-04-16) - 288b
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-07-21) - 288b
-
legacy (2006-07-21) - 288a
-
legacy (2006-08-16) - 287
-
legacy (2006-08-16) - 363a
-
legacy (2006-09-01) - 288b
-
memorandum-articles (2006-08-17) - MEM/ARTS
-
legacy (2006-08-22) - 225
-
legacy (2006-08-23) - 288a
-
resolution (2006-08-17) - RESOLUTIONS
-
legacy (2006-05-03) - 225
keyboard_arrow_right 2005
-
incorporation-company (2005-06-28) - NEWINC