-
MARTEL LIMITED - Birchin Court, 20 Birchin Lane, London, EC3V 9DJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05435479
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Birchin Court
- 20 Birchin Lane
- London
- EC3V 9DJ Birchin Court, 20 Birchin Lane, London, EC3V 9DJ UK
Management
- Geschäftsführung
- REPELOWICZ, Denis
- REPELOWICZ, Damien
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.04.2005
- Alter der Firma 2005-04-26 19 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Denis Repelowicz
- Mr Damien Repelowicz
- Ms Marine Repelowicz
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-28
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-04-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-10
- Letzte Einreichung: 2021-01-27
-
MARTEL LIMITED Firmenbeschreibung
- MARTEL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05435479. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.04.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.04.2013.Die Firma kann schriftlich über Birchin Court erreicht werden.
Jetzt sichern MARTEL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Martel Limited - Birchin Court, 20 Birchin Lane, London, EC3V 9DJ, Grossbritannien
- 2005-04-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MARTEL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-02-03) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-19) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-01-29) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-01-29) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-29) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-01-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2016-08-10) - DISS16(SOAS)
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-27) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-01-29) - AA01
-
gazette-notice-compulsory (2016-06-28) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-08) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-31) - TM02
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-11-09) - DISS40
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-10) - AD01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2014-08-05) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-07) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2013-09-30) - CH04
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-23) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-21) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-05-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2010-01-28) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-01-28) - 288a
-
legacy (2009-04-28) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-02-05) - AA
-
legacy (2009-06-26) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-17) - 287
-
legacy (2008-12-16) - 288b
-
legacy (2008-04-28) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2007-07-06) - AA
-
legacy (2007-05-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2006-05-23) - AA
-
legacy (2006-05-10) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-05-04) - 288a
-
legacy (2005-05-04) - 288b
-
incorporation-company (2005-04-26) - NEWINC