-
MAC CONSULTANTS UK LTD - ROSTRONS, Yare House 62-64, Thorpe Road, Norwich, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05380922
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- ROSTRONS
- Yare House 62-64
- Thorpe Road
- Norwich
- NR1 1RY ROSTRONS, Yare House 62-64, Thorpe Road, Norwich, NR1 1RY UK
Management
- Geschäftsführung
- MATTHEWSON, Alexander Neil
- MATTHEWSON, Deborah Roselyn Simone
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.03.2005
- Gelöscht am:
- 2020-11-17
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Pinnacle Communications Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-13
- Letzte Einreichung: 2020-03-02
-
MAC CONSULTANTS UK LTD Firmenbeschreibung
- MAC CONSULTANTS UK LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05380922. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.03.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Rostrons erreicht werden.
Jetzt sichern MAC CONSULTANTS UK LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mac Consultants Uk Ltd - ROSTRONS, Yare House 62-64, Thorpe Road, Norwich, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MAC CONSULTANTS UK LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-09-23) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-02-26) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-08-19) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-09-01) - GAZ1(A)
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-11-17) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-04-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-04-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-06) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-14) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-07) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-13) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-10-11) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-24) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-13) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-08-13) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-07-20) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-20) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-03) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-13) - AA
-
legacy (2009-03-25) - 287
-
legacy (2009-03-24) - 288c
-
legacy (2009-03-16) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-10-28) - AA
-
legacy (2008-05-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-09-08) - AA
-
legacy (2007-03-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-04-25) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-10-26) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
incorporation-company (2005-03-02) - NEWINC