-
RENEWAL NEW BERMONDSEY TWO LIMITED - Roof Top Guild House, Rollins Street, London, SE15 1EP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05344895
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Roof Top Guild House
- Rollins Street
- London
- SE15 1EP Roof Top Guild House, Rollins Street, London, SE15 1EP UK
Management
- Geschäftsführung
- MALIK, Jordana Soraya Fatima
- MCCLURE, Simon
- Prokuristen
- ANGELOVA, Martina
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.01.2005
- Alter der Firma 2005-01-27 19 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2017-01-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-10
- Letzte Einreichung: 2020-01-27
-
RENEWAL NEW BERMONDSEY TWO LIMITED Firmenbeschreibung
- RENEWAL NEW BERMONDSEY TWO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05344895. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.01.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.01.2017.Die Firma kann schriftlich über Roof Top Guild House erreicht werden.
Jetzt sichern RENEWAL NEW BERMONDSEY TWO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Renewal New Bermondsey Two Limited - Roof Top Guild House, Rollins Street, London, SE15 1EP, Grossbritannien
- 2005-01-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RENEWAL NEW BERMONDSEY TWO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-09-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-09-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-07-28) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-06-27) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-06-27) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-10) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-30) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-01-31) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-12) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-09-24) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-notice-compulsory (2014-12-30) - GAZ1
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-12-03) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-20) - AR01
-
change-sail-address-company (2014-02-13) - AD02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-07-10) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-10-03) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-02-10) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-02-10) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-10-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-08-18) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-09) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-02-06) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-12) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-16) - 403a
-
legacy (2008-08-13) - 225
-
accounts-with-accounts-type-small (2008-07-31) - AA
-
legacy (2008-03-14) - 395
-
legacy (2008-03-10) - 288c
-
legacy (2008-01-31) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-03-07) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-03-21) - AA
-
legacy (2007-10-29) - 288b
-
legacy (2007-10-29) - 288a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-12) - 395
-
legacy (2006-03-13) - 363a
-
resolution (2006-01-27) - RESOLUTIONS
-
legacy (2006-01-25) - 288a
-
legacy (2006-01-21) - 395
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-04-18) - 288a
-
legacy (2005-01-28) - 288b
-
incorporation-company (2005-01-27) - NEWINC