-
THE OXFORDSHIRE PRESS LIMITED - 2nd Floor Curzon House, 24 High Street Banstead, Surrey, SM7 2LJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05319086
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor Curzon House
- 24 High Street Banstead
- Surrey
- SM7 2LJ 2nd Floor Curzon House, 24 High Street Banstead, Surrey, SM7 2LJ UK
Management
- Geschäftsführung
- GIBSON, David Andrew
- GIBSON, Elizabeth Joy
- Prokuristen
- GIBSON, David Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.12.2004
- Alter der Firma 2004-12-22 19 Jahre
- SIC/NACE
- 58141
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David Andrew Gibson
- Mrs Elizabeth Joy Gibson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PELLMONT LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-04
- Letzte Einreichung: 2020-12-21
-
THE OXFORDSHIRE PRESS LIMITED Firmenbeschreibung
- THE OXFORDSHIRE PRESS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05319086. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.12.2004 registriert. THE OXFORDSHIRE PRESS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PELLMONT LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "58141" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor Curzon House erreicht werden.
Jetzt sichern THE OXFORDSHIRE PRESS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The Oxfordshire Press Limited - 2nd Floor Curzon House, 24 High Street Banstead, Surrey, SM7 2LJ, Grossbritannien
- 2004-12-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE OXFORDSHIRE PRESS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-15) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-01-31) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-18) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-16) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-01-16) - CH03
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-04-12) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-04-12) - CH03
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-16) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-03) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-09-03) - CH03
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-15) - AA
-
legacy (2009-09-11) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-05-01) - AA
-
legacy (2009-01-09) - 363a
-
legacy (2009-01-09) - 288c
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-03-26) - AA
-
legacy (2008-01-15) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-04-25) - AA
-
legacy (2007-01-25) - 363a
-
legacy (2007-09-07) - 395
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-05-04) - AA
-
legacy (2006-01-11) - 363a
-
legacy (2006-01-11) - 287
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-04-16) - 395
-
legacy (2005-01-31) - 287
-
legacy (2005-01-31) - 288b
-
legacy (2005-01-31) - 288a
-
legacy (2005-01-19) - 225
-
legacy (2005-01-19) - 88(2)R
-
certificate-change-of-name-company (2005-01-18) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2004
-
incorporation-company (2004-12-22) - NEWINC