-
STRUCTURAL PLANT SERVICES LIMITED - 21 Water Street, Skipton, North Yorkshire, BD23 1PQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05296263
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 21 Water Street
- Skipton
- North Yorkshire
- BD23 1PQ 21 Water Street, Skipton, North Yorkshire, BD23 1PQ UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- SANDERSON, Bryony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.11.2004
- Alter der Firma 2004-11-25 19 Jahre
- SIC/NACE
- 43991
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Terence Michael Dyson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-14
- Letzte Einreichung: 2020-01-31
-
STRUCTURAL PLANT SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- STRUCTURAL PLANT SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05296263. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.11.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43991" registriert. und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 21/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.01.2012.Die Firma kann schriftlich über 21 Water Street erreicht werden.
Jetzt sichern STRUCTURAL PLANT SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Structural Plant Services Limited - 21 Water Street, Skipton, North Yorkshire, BD23 1PQ, Grossbritannien
- 2004-11-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STRUCTURAL PLANT SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-07) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-02) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-02-02) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-02-02) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-07-17) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-19) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-03-15) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-03-28) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-04-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-09) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-15) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-15) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-03-15) - CH04
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-04-20) - AA
-
legacy (2009-03-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-02) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2008-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-04) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2006-08-08) - AA
-
legacy (2006-08-08) - 225
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-10) - 363a
-
legacy (2005-11-10) - 288a
-
legacy (2005-11-10) - 288b
-
legacy (2005-11-10) - 190
-
legacy (2005-11-10) - 353
-
legacy (2005-11-10) - 287
keyboard_arrow_right 2004
-
incorporation-company (2004-11-25) - NEWINC