-
AFTERSHOCK (WHOLESALE) LIMITED - 63-65 Mortimer Street, London, W1W 7UB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05282783
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 63-65 Mortimer Street
- London
- W1W 7UB 63-65 Mortimer Street, London, W1W 7UB UK
Management
- Geschäftsführung
- HARJANI, Hiro Narraindas
- Prokuristen
- HARJANI, Radhika
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.11.2004
- Gelöscht am:
- 2021-01-22
- SIC/NACE
- 46420
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-01-31
- Letzte Einreichung: 2012-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-08-12
- Letzte Einreichung:
-
AFTERSHOCK (WHOLESALE) LIMITED Firmenbeschreibung
- AFTERSHOCK (WHOLESALE) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05282783. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.11.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46420" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 63-65 Mortimer Street erreicht werden.
Jetzt sichern AFTERSHOCK (WHOLESALE) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Aftershock (Wholesale) Limited - 63-65 Mortimer Street, London, W1W 7UB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AFTERSHOCK (WHOLESALE) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-01-22) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-10-22) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-12) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-02-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-02-08) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-02-17) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-02-17) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2015-02-23) - 4.68
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-disclaimer-notice (2014-02-04) - F10.2
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-01) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-06-27) - TM01
-
resolution (2013-12-18) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2013-12-18) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2013-12-18) - 4.20
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-27) - AR01
-
legacy (2012-08-01) - MG02
-
legacy (2012-07-26) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-04-12) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-04-12) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-29) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-08) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-24) - 395
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-26) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-small (2008-04-09) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-16) - 363a
-
legacy (2007-11-20) - 225
-
legacy (2007-02-28) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-11-20) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-18) - 225
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2006-10-16) - AA
-
legacy (2006-08-04) - 288a
-
legacy (2006-02-10) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-07) - 287
-
legacy (2005-11-28) - 288b
-
legacy (2005-11-28) - 288a
-
legacy (2005-03-08) - 287
keyboard_arrow_right 2004
-
incorporation-company (2004-11-10) - NEWINC