-
INN TAKE (UK) LIMITED - 4th Floor 4 Victoria Square, St Albans, Hertfordshire, AL1 3TF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05264476
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor 4 Victoria Square
- St Albans
- Hertfordshire
- AL1 3TF 4th Floor 4 Victoria Square, St Albans, Hertfordshire, AL1 3TF UK
Management
- Geschäftsführung
- HARTHEN, Joseph
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.10.2004
- Gelöscht am:
- 2021-04-22
- SIC/NACE
- 7487
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2010-12-31
- Letzte Einreichung: 2009-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2011-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-02-14
- Letzte Einreichung:
-
INN TAKE (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- INN TAKE (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05264476. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.10.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "7487" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2009 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.01.2011.Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor 4 Victoria Square erreicht werden.
Jetzt sichern INN TAKE (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Inn Take (Uk) Limited - 4th Floor 4 Victoria Square, St Albans, Hertfordshire, AL1 3TF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu INN TAKE (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-04-22) - GAZ2
-
liquidation-compulsory-return-final-meeting (2021-01-22) - WU15
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-05-19) - WU07
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2019-06-04) - WU07
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2018-05-18) - WU07
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-miscellaneous (2017-05-31) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-09) - AD01
-
liquidation-miscellaneous (2016-04-28) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-miscellaneous (2015-07-10) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2014
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2014-04-17) - 4.31
-
liquidation-miscellaneous (2014-03-04) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2013
-
liquidation-miscellaneous (2013-02-21) - LIQ MISC
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2013-02-21) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2012
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2012-03-05) - 4.31
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2012-02-28) - COCOMP
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-11) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-27) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-02-11) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2011-02-11) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-01-27) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-11) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-11) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2011-07-05) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2011-07-16) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-02) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2010-06-21) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2010-06-21) - AP03
-
auditors-resignation-limited-company (2010-06-07) - AA03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-06-07) - AD01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2010-05-24) - AAMD
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2010-05-05) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-05-04) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2010-05-04) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-07) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2009-06-24) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-small (2009-06-23) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2009-05-19) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2009-05-16) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-31) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-12-31) - AA
-
legacy (2007-10-23) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-20) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-12-14) - AA
-
legacy (2006-10-09) - 288c
-
legacy (2006-01-18) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-18) - 288a
-
legacy (2005-11-18) - 288b
-
legacy (2005-04-20) - 287
-
legacy (2005-04-20) - 225
-
legacy (2005-03-18) - 287
keyboard_arrow_right 2004
-
incorporation-company (2004-10-20) - NEWINC