-
T & N CLINCH LIMITED - 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05214800
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 109 Swan Street
- Sileby
- LE12 7NN 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- CLINCH, Nicholas Darren Stewart
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.08.2004
- Gelöscht am:
- 2021-02-19
- SIC/NACE
- 46410
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas Clinch
- Mr Nicholas Clinch
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-09-07
- Letzte Einreichung: 2018-08-24
-
T & N CLINCH LIMITED Firmenbeschreibung
- T & N CLINCH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05214800. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 25.08.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46410" registriert. und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 109 Swan Street erreicht werden.
Jetzt sichern T & N CLINCH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: T & N Clinch Limited - 109 Swan Street, Sileby, LE12 7NN, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu T & N CLINCH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-02-19) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-11-19) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-08) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-07) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-03-06) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-06) - 600
-
resolution (2019-03-06) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-10-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-21) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-05) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-12) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-02) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-02) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-09-02) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-09-02) - CH03
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-02) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-02) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-02) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-18) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-10-15) - AA
-
legacy (2009-09-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-08) - 363a
-
legacy (2008-09-08) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-12) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-09-12) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-06) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-09-07) - 363a
-
legacy (2005-02-17) - 225
keyboard_arrow_right 2004
-
incorporation-company (2004-08-25) - NEWINC