-
TRADING CARDS 24 7 LIMITED - Dephna House, 24-26 Arcadia Avenue, London, N3 2JU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05151228
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Dephna House
- 24-26 Arcadia Avenue
- London
- N3 2JU Dephna House, 24-26 Arcadia Avenue, London, N3 2JU UK
Management
- Geschäftsführung
- HIBBERT, Simon James
- Prokuristen
- HIBBERT, Simon James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.06.2004
- Gelöscht am:
- 2020-08-20
- SIC/NACE
- 47650
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-03-31
- Letzte Einreichung: 2012-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-06-25
- Letzte Einreichung:
-
TRADING CARDS 24 7 LIMITED Firmenbeschreibung
- TRADING CARDS 24 7 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05151228. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.06.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47650" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Dephna House erreicht werden.
Jetzt sichern TRADING CARDS 24 7 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trading Cards 24 7 Limited - Dephna House, 24-26 Arcadia Avenue, London, N3 2JU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRADING CARDS 24 7 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-08-20) - GAZ2
-
liquidation-compulsory-return-final-meeting (2020-05-20) - WU15
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2019-03-29) - WU07
-
liquidation-compulsory-defer-dissolution (2019-04-08) - L64.04
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2018-04-11) - WU07
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-miscellaneous (2017-04-04) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-compulsory-defer-dissolution (2016-03-29) - L64.04
-
liquidation-compulsory-completion (2016-03-21) - L64.07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-11) - AD01
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2016-03-10) - 4.31
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-31) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2015-04-07) - GAZ1
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2015-05-07) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-07) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-08-05) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-02) - AR01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-06-10) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2014-04-29) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2013-09-18) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2013-07-02) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-09) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2011-08-06) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-04) - AR01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2011-02-16) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2010
-
gazette-notice-compulsary (2010-01-19) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-07) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2010-04-10) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-14) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-12) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-29) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-29) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2010-12-07) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-07) - 363a
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2009-07-28) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-25) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2009-04-28) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-08-15) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-08-12) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
incorporation-company (2004-06-11) - NEWINC