-
BMV DISTRIBUTORS LIMITED - C/O Neum Insolvency Suite 9 Amba House, 15 College Road, Harrow, Middlesex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05105439
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Neum Insolvency Suite 9 Amba House
- 15 College Road
- Harrow
- Middlesex
- HA1 1BA C/O Neum Insolvency Suite 9 Amba House, 15 College Road, Harrow, Middlesex, HA1 1BA UK
Management
- Geschäftsführung
- MADHANI, Rajesh
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.04.2004
- Gelöscht am:
- 2021-03-30
- SIC/NACE
- 46360
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Rajesh Madhani
- Mrs Anita Madhani
- Mr Rajesh Madhani
- Mrs Anita Madhani
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-04-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-08-22
- Letzte Einreichung: 2018-08-08
-
BMV DISTRIBUTORS LIMITED Firmenbeschreibung
- BMV DISTRIBUTORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05105439. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 19.04.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46360" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.04.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Neum Insolvency Suite 9 Amba House erreicht werden.
Jetzt sichern BMV DISTRIBUTORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bmv Distributors Limited - C/O Neum Insolvency Suite 9 Amba House, 15 College Road, Harrow, Middlesex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BMV DISTRIBUTORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-03-30) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-12-30) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-16) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-20) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-23) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-08) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-16) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-25) - MR04
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-09-12) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-09-12) - 600
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-11) - AA01
-
resolution (2018-09-12) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-20) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-28) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-08-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-05-14) - AA
-
legacy (2009-04-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-07-21) - AA
-
legacy (2008-07-18) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-06-08) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-07-10) - AA
-
legacy (2006-06-26) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-08-03) - 403a
-
legacy (2005-04-21) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2005-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-09-03) - 225
-
legacy (2004-08-11) - 395
-
legacy (2004-06-22) - 395
-
incorporation-company (2004-04-19) - NEWINC
-
legacy (2004-05-17) - 288b