-
WARLEGGAN FINANCE LTD - Robert Denholm House, Bletchingley Road, Nutfield, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05102391
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Robert Denholm House
- Bletchingley Road
- Nutfield
- Surrey
- RH1 4HW Robert Denholm House, Bletchingley Road, Nutfield, Surrey, RH1 4HW UK
Management
- Geschäftsführung
- BEST, Christopher Howard
- Prokuristen
- BEST, Christopher Howard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.04.2004
- Gelöscht am:
- 2020-06-23
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Christopher Howard Best
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-11-14
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-04-27
- Letzte Einreichung: 2018-04-13
-
WARLEGGAN FINANCE LTD Firmenbeschreibung
- WARLEGGAN FINANCE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05102391. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 15.04.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Robert Denholm House erreicht werden.
Jetzt sichern WARLEGGAN FINANCE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Warleggan Finance Ltd - Robert Denholm House, Bletchingley Road, Nutfield, Surrey, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WARLEGGAN FINANCE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-06-23) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-03-23) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-03-06) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-06) - 600
-
resolution (2019-03-06) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-04) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-14) - PSC04
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-08-14) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-02) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-sail-address-company-with-old-address (2013-04-25) - AD02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-01-22) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-17) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-09-17) - CH03
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-08) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-05-08) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-05-08) - CH01
-
change-sail-address-company (2012-05-08) - AD02
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-09-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-19) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-03-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-27) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-01) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-27) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-05-07) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-12-18) - AA
-
legacy (2007-04-16) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-01-22) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-04-20) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-03-01) - AA
-
legacy (2006-02-16) - 225
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-05-31) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
incorporation-company (2004-04-15) - NEWINC