-
HINDSITE CONSTRUCTION LIMITED - Goodwood House, Blackbrook Park Avenue, Taunton, Somerset, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05097478
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Goodwood House
- Blackbrook Park Avenue
- Taunton
- Somerset
- TA1 2PX Goodwood House, Blackbrook Park Avenue, Taunton, Somerset, TA1 2PX UK
Management
- Geschäftsführung
- COLEMON, Philip Colin
- HILLIER, Jonathan
- Prokuristen
- HILLIER, Jonathan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.04.2004
- Alter der Firma 2004-04-07 20 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- BASHELFCO 2832 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-07-31
- Letzte Einreichung: 2013-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-04-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-04-21
- Letzte Einreichung:
-
HINDSITE CONSTRUCTION LIMITED Firmenbeschreibung
- HINDSITE CONSTRUCTION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05097478. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.04.2004 registriert. HINDSITE CONSTRUCTION LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BASHELFCO 2832 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2013 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.04.2013.Die Firma kann schriftlich über Goodwood House erreicht werden.
Jetzt sichern HINDSITE CONSTRUCTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hindsite Construction Limited - Goodwood House, Blackbrook Park Avenue, Taunton, Somerset, Grossbritannien
- 2004-04-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HINDSITE CONSTRUCTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-05-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-13) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-05-08) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-05-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-05-18) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-05-17) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-voluntary-constitution-liquidation-committee (2015-04-10) - 4.48
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-25) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-03-24) - 600
-
resolution (2015-03-24) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-03-24) - 4.20
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-05) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-05-23) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-05-23) - CH03
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-29) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-05-12) - AA
-
legacy (2009-04-23) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-06-20) - 287
-
legacy (2008-05-21) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-03-10) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-20) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-07-24) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-05-18) - AA
-
legacy (2006-04-21) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-04-28) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2004-11-16) - AA
-
legacy (2004-10-30) - 225
-
legacy (2004-09-13) - 287
-
legacy (2004-07-27) - 88(2)R
-
legacy (2004-07-27) - 225
-
legacy (2004-07-27) - 288b
-
legacy (2004-07-27) - 288a
-
certificate-change-of-name-company (2004-07-21) - CERTNM
-
legacy (2004-11-16) - 225
-
incorporation-company (2004-04-07) - NEWINC