-
ABILO (UK) LIMITED - 2nd Floor Stc House, 7 Elmfield Road, Bromley, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05070329
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor Stc House
- 7 Elmfield Road
- Bromley
- Kent
- BR1 1LT 2nd Floor Stc House, 7 Elmfield Road, Bromley, Kent, BR1 1LT UK
Management
- Geschäftsführung
- PETKOV, Plamen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.03.2004
- Gelöscht am:
- 2020-02-25
- SIC/NACE
- 46120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Plamen Petkov
- Plamen Petkov
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-11
-
ABILO (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- ABILO (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05070329. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.03.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46120" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor Stc House erreicht werden.
Jetzt sichern ABILO (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Abilo (Uk) Limited - 2nd Floor Stc House, 7 Elmfield Road, Bromley, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ABILO (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-02-25) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-12) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-24) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-10-24) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-24) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-20) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-16) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-10-12) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-27) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-09-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-09-05) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-secretary-company-with-name (2012-12-18) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-11) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-01-11) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2012-01-10) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-02-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-09-25) - AA
-
miscellaneous (2010-06-15) - MISC
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-full (2009-08-24) - AA
-
legacy (2009-03-24) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-full (2008-10-23) - AA
-
legacy (2008-10-20) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-full (2008-06-10) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-05-08) - 363s
-
legacy (2007-05-24) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-full (2007-07-23) - AA
-
legacy (2007-05-24) - 288b
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-06-23) - 363s
-
legacy (2006-01-25) - 288a
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-full (2005-11-03) - AA
-
legacy (2005-05-13) - 363s
-
legacy (2005-03-10) - 395
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-04-23) - 225
-
legacy (2004-04-06) - 288a
-
legacy (2004-03-31) - 288b
-
incorporation-company (2004-03-11) - NEWINC