-
DAMACOL LIMITED - Cholmondeley House, Dee Hills Park, Chester, CH3 5AR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05045146
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cholmondeley House
- Dee Hills Park
- Chester
- CH3 5AR Cholmondeley House, Dee Hills Park, Chester, CH3 5AR UK
Management
- Geschäftsführung
- GARNHAM, David Michael
- WILLIAMS, Mark John
- Prokuristen
- GARNHAM, David Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.02.2004
- Gelöscht am:
- 2022-09-20
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mark John Williams
- Mr David Michael Garnham
- Mark John Williams
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-11-30
- Letzte Einreichung: 2021-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-02
- Letzte Einreichung: 2021-02-16
-
DAMACOL LIMITED Firmenbeschreibung
- DAMACOL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05045146. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 16.02.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Cholmondeley House erreicht werden.
Jetzt sichern DAMACOL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Damacol Limited - Cholmondeley House, Dee Hills Park, Chester, CH3 5AR, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DAMACOL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-19) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-04-30) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-22) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-22) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-11) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-05-11) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-04-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-29) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-22) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-28) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-03-13) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-13) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-14) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-22) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-02-22) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-02-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-17) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-09-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-29) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-02-23) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-11-02) - AA
-
legacy (2008-10-17) - 88(2)
-
legacy (2008-03-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-03-21) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-01-03) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-12-10) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-03-09) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2005-12-22) - AA
-
legacy (2005-03-17) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-06-16) - 395
-
legacy (2004-03-16) - 288a
-
legacy (2004-03-16) - 88(2)R
-
legacy (2004-03-10) - 288a
-
legacy (2004-03-10) - 287
-
legacy (2004-02-25) - 288b
-
incorporation-company (2004-02-16) - NEWINC