-
SCANDINAVIAN LOG CABINS DIRECT LIMITED - 34, New House 67-68 Hatton Garden, London, EC1N 8JY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04982890
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 34
- New House 67-68 Hatton Garden
- London
- EC1N 8JY 34, New House 67-68 Hatton Garden, London, EC1N 8JY UK
Management
- Geschäftsführung
- BARBER, Mark Spencer
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.12.2003
- Gelöscht am:
- 2020-09-29
- SIC/NACE
- 46130
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Smith
- Mr Mark Smith
- Mr Mark Barber
- Mr Mark Barber
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-12-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-12-16
- Letzte Einreichung: 2018-12-02
-
SCANDINAVIAN LOG CABINS DIRECT LIMITED Firmenbeschreibung
- SCANDINAVIAN LOG CABINS DIRECT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04982890. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.12.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46130" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.12.2015.Die Firma kann schriftlich über 34 erreicht werden.
Jetzt sichern SCANDINAVIAN LOG CABINS DIRECT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Scandinavian Log Cabins Direct Limited - 34, New House 67-68 Hatton Garden, London, EC1N 8JY, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SCANDINAVIAN LOG CABINS DIRECT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-03-17) - GAZ1(A)
-
gazette-notice-compulsory (2020-02-25) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-03-04) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-03-09) - DS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-03-07) - DISS40
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-08-16) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-18) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-22) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-12-20) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-12-19) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-05-11) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-06) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-30) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-05-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-10) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-12-10) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-31) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-02) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-08-10) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-08-08) - AA
-
gazette-notice-compulsary (2013-08-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-06-27) - AA
-
termination-director-company-with-name (2011-04-27) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-04-26) - TM02
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-06-16) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-13) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-13) - CH01
-
legacy (2009-09-29) - 395
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-05-06) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-04) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-08-30) - AA
-
legacy (2007-01-23) - 363s
-
legacy (2007-12-05) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-06-29) - 288a
-
legacy (2006-06-28) - 88(2)R
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-04-11) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-28) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2005-04-21) - AA
-
legacy (2005-01-24) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-01-05) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-12-09) - 287
-
legacy (2003-12-09) - 288a
-
legacy (2003-12-09) - 288b
-
incorporation-company (2003-12-02) - NEWINC