-
CHROMEGATE LIMITED - Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04977525
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Greg's Building
- 1 Booth Street
- Manchester
- M2 4DU Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU UK
Management
- Geschäftsführung
- DORAN, James Donald
- TOFFOLO, Antonio Peter
- TRAVIS, Henry Stuart
- Prokuristen
- TRAVIS, Henry Stuart
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.11.2003
- Gelöscht am:
- 2012-12-03
- SIC/NACE
- 7020
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- insolvency-proceedings
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2012-01-31
- Letzte Einreichung: 2010-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2010-11-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-12-10
- Letzte Einreichung:
-
CHROMEGATE LIMITED Firmenbeschreibung
- CHROMEGATE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04977525. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.11.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "7020" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2010 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.11.2010.Die Firma kann schriftlich über Greg's Building erreicht werden.
Jetzt sichern CHROMEGATE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Chromegate Limited - Greg's Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
- 2003-11-26
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHROMEGATE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-miscellaneous (2020-07-22) - LIQ MISC
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-16) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-release-of-liquidator-by-secretary-of-state (2020-07-16) - LIQ12
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-07-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-23) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-05-12) - 600
-
resolution (2017-05-12) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2017-05-12) - 4.20
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
restoration-order-of-court (2016-10-20) - AC92
keyboard_arrow_right 2012
-
gazette-dissolved-liquidation (2012-12-03) - GAZ2
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2012-09-03) - 2.35B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2012-03-02) - 2.24B
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2012-03-02) - 2.31B
keyboard_arrow_right 2011
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2011-10-13) - 2.24B
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-03-01) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-07) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2011-03-08) - 2.12B
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2011-10-18) - 2.16B
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2011-05-16) - 2.23B
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-14) - AR01
-
legacy (2010-05-21) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-12) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-01-29) - 363a
-
legacy (2009-03-30) - 287
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-27) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-03-15) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-09) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-01-31) - AA
-
legacy (2006-01-05) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-06-18) - 403a
-
legacy (2005-09-19) - 288b
-
legacy (2005-05-21) - 395
-
legacy (2005-05-18) - 395
-
legacy (2005-01-11) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-05-13) - 287
-
legacy (2004-05-13) - 88(2)R
-
legacy (2004-03-09) - 288b
-
legacy (2004-07-14) - 225
-
legacy (2004-03-09) - 288a
-
legacy (2004-05-18) - 395
-
legacy (2004-05-28) - 395
-
legacy (2004-06-08) - 288a
keyboard_arrow_right 2003
-
incorporation-company (2003-11-26) - NEWINC