-
ROSEDALE INK LIMITED - 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04965453
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2-3 Winckley Court Chapel Street
- Preston
- PR1 8BU 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU UK
Management
- Geschäftsführung
- PILLING, Richard Matthew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.11.2003
- Gelöscht am:
- 2022-05-15
- SIC/NACE
- 47789
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard Matthew Pilling
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-01
- Letzte Einreichung: 2020-11-17
-
ROSEDALE INK LIMITED Firmenbeschreibung
- ROSEDALE INK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04965453. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 17.11.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47789" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2-3 Winckley Court Chapel Street erreicht werden.
Jetzt sichern ROSEDALE INK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rosedale Ink Limited - 2-3 Winckley Court Chapel Street, Preston, PR1 8BU, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ROSEDALE INK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2021-08-14) - LIQ10
-
resolution (2021-01-07) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-01-07) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-07) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-01-07) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-13) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-14) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-14) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-30) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-11-25) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-08) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-13) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-12) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-14) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-24) - 363a
-
legacy (2008-11-24) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-07-25) - AA
-
legacy (2007-12-06) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-07-10) - AA
-
legacy (2006-12-10) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-21) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-11-17) - 363s
-
legacy (2004-05-01) - 395
-
legacy (2004-03-02) - 287
-
legacy (2004-02-09) - 225
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-12-16) - 88(2)R
-
legacy (2003-11-17) - 288b
-
incorporation-company (2003-11-17) - NEWINC