-
VINOCITY LIMITED - 4 & 5 The Cedars Apex 12 Old Ipswich Road, Ardleigh, Colchester, CO7 7QR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04965243
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 & 5 The Cedars Apex 12 Old Ipswich Road
- Ardleigh
- Colchester
- CO7 7QR 4 & 5 The Cedars Apex 12 Old Ipswich Road, Ardleigh, Colchester, CO7 7QR UK
Management
- Geschäftsführung
- WHEELER, Johnny Blyth
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.11.2003
- Gelöscht am:
- 2015-10-20
- SIC/NACE
- 70100
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LAY & WHEELER LEISURE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-03-31
- Letzte Einreichung: 2014-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-12-01
- Letzte Einreichung:
-
VINOCITY LIMITED Firmenbeschreibung
- VINOCITY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04965243. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.11.2003 registriert. VINOCITY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LAY & WHEELER LEISURE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.11.2012.Die Firma kann schriftlich über 4 & 5 The Cedars Apex 12 Old Ipswich Road erreicht werden.
Jetzt sichern VINOCITY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vinocity Limited - 4 & 5 The Cedars Apex 12 Old Ipswich Road, Ardleigh, Colchester, CO7 7QR, Grossbritannien
- 2003-11-17
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VINOCITY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-07-21) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-08-03) - GAZ1(A)
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-09-11) - SOAS(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
restoration-order-of-court (2020-10-20) - AC92
keyboard_arrow_right 2015
-
gazette-notice-voluntary (2015-07-07) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2015-06-26) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-10) - AA
-
gazette-dissolved-voluntary (2015-10-20) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-18) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-18) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-21) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2013-09-21) - DISS16(SOAS)
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-15) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-10-02) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-07-02) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-13) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2012-12-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-15) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-05-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-06-24) - 288b
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-12-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-05-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-02-02) - AA
-
legacy (2008-11-28) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-12-31) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-02-06) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-06) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-03-07) - AA
-
legacy (2006-02-10) - 287
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-22) - 363s
-
legacy (2005-03-02) - 88(2)R
-
certificate-change-of-name-company (2005-02-09) - CERTNM
-
legacy (2005-01-04) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
memorandum-articles (2004-04-06) - MEM/ARTS
-
legacy (2004-07-27) - 395
-
legacy (2004-07-28) - 395
-
legacy (2004-08-02) - 288a
-
legacy (2004-08-02) - 225
-
legacy (2004-08-02) - 288b
-
resolution (2004-09-10) - RESOLUTIONS
-
legacy (2004-09-10) - 123
-
legacy (2004-08-02) - 287
-
certificate-change-of-name-company (2004-04-01) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2003
-
incorporation-company (2003-11-17) - NEWINC