-
MACLEAN & SPEIRS BLASTING (SOUTH) LIMITED - 10, Western Road, Romford, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04942186
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 10
- Western Road
- Romford
- Essex
- RM1 3JT 10, Western Road, Romford, Essex, RM1 3JT UK
Management
- Geschäftsführung
- MCLOUGHLIN, Kevin Michael Martin
- Prokuristen
- HAMMERSLEY, George Douglas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.10.2003
- Gelöscht am:
- 2020-09-29
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kevin Mcloughlin
- Mr Kenneth Ronald Stewart
- Mr Kevin Michael Martin Mcloughlin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- 00E53 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-25
- Letzte Einreichung: 2019-10-11
-
MACLEAN & SPEIRS BLASTING (SOUTH) LIMITED Firmenbeschreibung
- MACLEAN & SPEIRS BLASTING (SOUTH) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04942186. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.10.2003 registriert. MACLEAN & SPEIRS BLASTING (SOUTH) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen 00E53 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 10 erreicht werden.
Jetzt sichern MACLEAN & SPEIRS BLASTING (SOUTH) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Maclean & Speirs Blasting (South) Limited - 10, Western Road, Romford, Essex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MACLEAN & SPEIRS BLASTING (SOUTH) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-03-17) - GAZ1(A)
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-01-23) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-03-10) - DS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-08-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-09-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-09-24) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2013-03-14) - CERTNM
-
resolution (2013-03-14) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-19) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-02-11) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2013-02-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-02-11) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-08-13) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-02) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-08-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-09-15) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-07-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2010-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-22) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-02-06) - AA
-
legacy (2008-10-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-01-31) - AA
-
legacy (2007-10-31) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-10-23) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-10-12) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-10-21) - 363s
-
legacy (2004-08-27) - 225
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-12-24) - 88(2)R
-
legacy (2003-10-23) - 288b
-
incorporation-company (2003-10-23) - NEWINC