-
FENOX (UK) LIMITED - Langdale House, 11 Marshalsea Road, London, SE1 1EN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04937992
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Langdale House
- 11 Marshalsea Road
- London
- SE1 1EN
- United Kingdom Langdale House, 11 Marshalsea Road, London, SE1 1EN, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- KHRYSTSICH, Uladzimir
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.10.2003
- Gelöscht am:
- 2020-02-04
- SIC/NACE
- 45310
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Vitaliy Arbuzov
- Vitaliy Arbuzov
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-07-31
- Letzte Einreichung: 2013-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-20
-
FENOX (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- FENOX (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04937992. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.10.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45310" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2013 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Langdale House erreicht werden.
Jetzt sichern FENOX (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fenox (Uk) Limited - Langdale House, 11 Marshalsea Road, London, SE1 1EN, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FENOX (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-02-04) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-22) - CS01
-
gazette-notice-voluntary (2019-11-19) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2019-11-07) - DS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-10) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-10) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-01-06) - SH03
-
gazette-notice-compulsory (2016-01-12) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-01-13) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-08) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-cancellation-shares (2015-12-07) - SH06
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-08) - AA
-
capital-alter-shares-redemption-statement-of-capital (2015-12-07) - SH02
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-28) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-02-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-20) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-28) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-20) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-08-02) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-20) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2009-10-20) - CH04
-
legacy (2009-08-11) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-16) - AA
-
legacy (2009-05-22) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-21) - 363a
-
legacy (2008-08-27) - 288a
-
legacy (2008-08-27) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-08-05) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-07-14) - AA
-
legacy (2007-11-02) - 287
-
legacy (2007-11-05) - 288c
-
legacy (2007-11-05) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-11-08) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-10-26) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-10-20) - 363a
-
legacy (2005-07-19) - 88(2)R
-
resolution (2005-06-25) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-03-10) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-11-22) - 363s
-
legacy (2004-03-12) - 88(2)R
-
legacy (2004-03-12) - 288a
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-10-30) - 288b
-
incorporation-company (2003-10-20) - NEWINC