-
REMINDER TIME LIMITED - Prospect House 5 Prospect House, Meridians Cross, Ocean Way, Southampton, SO14 3TJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04837554
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Prospect House 5 Prospect House
- Meridians Cross, Ocean Way
- Southampton
- SO14 3TJ Prospect House 5 Prospect House, Meridians Cross, Ocean Way, Southampton, SO14 3TJ UK
Management
- Geschäftsführung
- JEFFERY SYKES, Nicola, Dr
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.07.2003
- Alter der Firma 2003-07-18 20 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2012-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-09-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-10-13
- Letzte Einreichung:
-
REMINDER TIME LIMITED Firmenbeschreibung
- REMINDER TIME LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04837554. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.07.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.09.2013.Die Firma kann schriftlich über Prospect House 5 Prospect House erreicht werden.
Jetzt sichern REMINDER TIME LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Reminder Time Limited - Prospect House 5 Prospect House, Meridians Cross, Ocean Way, Southampton, SO14 3TJ, Grossbritannien
- 2003-07-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu REMINDER TIME LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2022-11-02) - WU07
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2021-10-21) - WU07
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2020-08-04) - WU04
-
liquidation-compulsory-removal-of-liquidator-by-court (2020-08-04) - WU14
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-10-22) - WU07
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2019-10-30) - WU07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2018-11-09) - WU07
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2018-11-09) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2017-12-07) - WU07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-31) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-miscellaneous (2016-10-31) - LIQ MISC
keyboard_arrow_right 2015
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2015-07-01) - COCOMP
-
gazette-notice-compulsory (2015-03-10) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-03-24) - DISS16(SOAS)
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2015-09-14) - 4.31
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-07-18) - TM02
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-satisfy-charge-full (2013-10-22) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-22) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-06) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-30) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-03-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-10-02) - 363a
-
legacy (2009-07-14) - 88(2)
-
legacy (2009-07-14) - 123
-
resolution (2009-07-14) - RESOLUTIONS
-
legacy (2009-05-26) - 363a
-
legacy (2009-04-23) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-09) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-11-06) - AA
-
legacy (2006-08-04) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-29) - 88(2)R
-
legacy (2005-07-12) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-05-24) - AA
-
legacy (2005-05-24) - 225
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-09-03) - 363s
-
legacy (2004-08-19) - 395
-
legacy (2004-06-15) - 287
-
legacy (2004-01-21) - 287
keyboard_arrow_right 2003
-
incorporation-company (2003-07-18) - NEWINC
-
legacy (2003-08-14) - 288a
-
legacy (2003-07-22) - 288b
-
resolution (2003-07-29) - RESOLUTIONS