-
R J S PRODUCTIONS LIMITED - HILLIER HOPKINS LLP, First Floor Radius House, 51 Clarendon Road, Watford, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04818302
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- HILLIER HOPKINS LLP
- First Floor Radius House
- 51 Clarendon Road
- Watford
- WD17 1HP HILLIER HOPKINS LLP, First Floor Radius House, 51 Clarendon Road, Watford, WD17 1HP UK
Management
- Geschäftsführung
- SCOTT, Robert James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.07.2003
- Alter der Firma 2003-07-02 21 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Robert James Scott
- Robert James Scott
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-16
- Letzte Einreichung: 2020-07-02
-
R J S PRODUCTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- R J S PRODUCTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04818302. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.07.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hillier Hopkins Llp erreicht werden.
Jetzt sichern R J S PRODUCTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: R J S Productions Limited - HILLIER HOPKINS LLP, First Floor Radius House, 51 Clarendon Road, Watford, Grossbritannien
- 2003-07-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu R J S PRODUCTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-08-05) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2021-07-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-04-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-07) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-03) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-04-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-27) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-08-17) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-12) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2013-11-12) - CH04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-11-12) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-11-09) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2013-10-29) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-21) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-15) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-15) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-07-15) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-29) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-08-27) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-05-13) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-17) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-05-10) - AA
-
legacy (2006-09-15) - 288c
-
legacy (2006-09-15) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-08-31) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-06-25) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-09-04) - 288a
-
legacy (2003-09-04) - 287
-
legacy (2003-07-14) - 288b
-
legacy (2003-07-14) - 287
-
incorporation-company (2003-07-02) - NEWINC