-
PEST & HYGIENE LIMITED - The Manor House, 260 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04727843
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Manor House
- 260 Ecclesall Road South
- Sheffield
- S11 9PS The Manor House, 260 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PS UK
Management
- Geschäftsführung
- SYKES, Brian Maurice
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.04.2003
- Gelöscht am:
- 2021-03-15
- SIC/NACE
- 81291
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Brian Maurice Sykes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- HPC (PEST CONTROL) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-02-28
- Letzte Einreichung: 2017-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-04-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-04-23
- Letzte Einreichung: 2017-04-09
-
PEST & HYGIENE LIMITED Firmenbeschreibung
- PEST & HYGIENE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04727843. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 09.04.2003 registriert. PEST & HYGIENE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HPC (PEST CONTROL) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "81291" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.04.2013.Die Firma kann schriftlich über The Manor House erreicht werden.
Jetzt sichern PEST & HYGIENE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pest & Hygiene Limited - The Manor House, 260 Ecclesall Road South, Sheffield, S11 9PS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PEST & HYGIENE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-03-15) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-12-15) - LIQ13
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-05-21) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-19) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-04-16) - 600
-
resolution (2018-04-16) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-04-16) - LIQ01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-03) - AR01
-
resolution (2016-11-30) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-11-10) - MR04
-
change-of-name-notice (2016-11-02) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-17) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-secretary-company-with-name (2013-06-06) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-02) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-10-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-04-28) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-28) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-18) - AA
-
legacy (2009-06-04) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-10-22) - AA
-
legacy (2008-08-01) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-12-30) - AA
-
legacy (2007-05-29) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-05-09) - 363s
-
legacy (2006-08-08) - 395
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-11-27) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-03-27) - AA
-
legacy (2006-12-14) - 123
-
legacy (2006-12-14) - 88(2)R
-
resolution (2006-12-14) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-04-20) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-01-26) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-11-18) - 225
-
legacy (2004-05-04) - 363s
-
legacy (2004-05-04) - 288b
-
legacy (2004-02-18) - 288a
keyboard_arrow_right 2003
-
incorporation-company (2003-04-09) - NEWINC
-
legacy (2003-07-24) - 288c
-
legacy (2003-07-24) - 287
-
legacy (2003-06-18) - 288a
-
legacy (2003-06-16) - 288a