-
M.J.S. AMUSEMENTS LIMITED - East Coast House, Galahad Road Beacon Park, Gorleston Great Yarmouth, Norfolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04676865
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- East Coast House
- Galahad Road Beacon Park
- Gorleston Great Yarmouth
- Norfolk
- NR31 7RU East Coast House, Galahad Road Beacon Park, Gorleston Great Yarmouth, Norfolk, NR31 7RU UK
Management
- Geschäftsführung
- SWANN, Marcelle
- SWANN, Ria Harriett
- Prokuristen
- SWANN, Marcelle
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.02.2003
- Alter der Firma 2003-02-25 21 Jahre
- SIC/NACE
- 93290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Marcelle Swann
- Mr Mitchell James Swann
- Mrs Marcelle Swann
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-10
- Letzte Einreichung: 2020-07-27
-
M.J.S. AMUSEMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- M.J.S. AMUSEMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04676865. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.02.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93290" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 25.02.2013.Die Firma kann schriftlich über East Coast House erreicht werden.
Jetzt sichern M.J.S. AMUSEMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: M.j.s. Amusements Limited - East Coast House, Galahad Road Beacon Park, Gorleston Great Yarmouth, Norfolk, Grossbritannien
- 2003-02-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu M.J.S. AMUSEMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-15) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-07-20) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-08-09) - SH08
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-11-06) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-26) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-25) - AA
-
resolution (2013-06-10) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2013-05-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-03-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date (2011-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-06-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date (2010-03-12) - AR01
-
legacy (2010-02-24) - MG01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-06-06) - AA
-
legacy (2009-03-11) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-06-30) - AA
-
legacy (2008-06-17) - 395
-
legacy (2008-03-28) - 363s
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-05-23) - AA
-
legacy (2007-03-24) - 363s
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-02-21) - 288a
-
legacy (2006-03-16) - 363s
-
legacy (2006-05-30) - 88(2)R
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-07-07) - AA
-
legacy (2006-07-13) - 287
-
legacy (2006-06-07) - 225
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-05-06) - AA
-
legacy (2005-03-11) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-06-21) - AA
-
legacy (2004-04-20) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-03-22) - 288a
-
legacy (2003-03-22) - 288b
-
incorporation-company (2003-02-25) - NEWINC