-
ABODE LONDON LIMITED - 24, Conduit Place, London, W2 1EP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04666404
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 24
- Conduit Place
- London
- W2 1EP 24, Conduit Place, London, W2 1EP UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIS, Ronald Ian
- SIDDIQUI, Shahzad
- TURTILL, Andrew Upton
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.02.2003
- Gelöscht am:
- 2020-05-21
- SIC/NACE
- 68310
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-11-30
- Letzte Einreichung: 2013-02-28
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-13
-
ABODE LONDON LIMITED Firmenbeschreibung
- ABODE LONDON LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04666404. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 13.02.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68310" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28/02/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.02.2013.Die Firma kann schriftlich über 24 erreicht werden.
Jetzt sichern ABODE LONDON LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Abode London Limited - 24, Conduit Place, London, W2 1EP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ABODE LONDON LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-05-21) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-02-21) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-06-27) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-03-07) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-27) - 600
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-03-05) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-03-01) - 4.68
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2016-03-03) - 4.68
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-09) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2015-01-08) - 600
-
resolution (2015-01-08) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2015-01-08) - 4.20
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-charge-whole-cease-and-release-with-charge-number (2014-11-20) - MR05
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-18) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-24) - AA
-
legacy (2009-04-28) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-12-17) - 288b
-
legacy (2008-09-22) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-12-25) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-12-20) - AA
-
legacy (2007-04-16) - 363a
-
legacy (2007-04-16) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-01-26) - 287
-
legacy (2006-02-16) - 363a
-
legacy (2006-05-04) - 288c
-
legacy (2006-05-04) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-12-28) - AA
-
legacy (2005-03-11) - 395
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-04-20) - 287
-
legacy (2004-04-20) - 288b
-
legacy (2004-04-26) - 287
-
legacy (2004-07-15) - 395
-
legacy (2004-05-19) - 363s
-
legacy (2004-05-26) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-12-13) - AA
-
legacy (2004-05-17) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-11-12) - 288a
-
legacy (2003-05-19) - 288a
-
legacy (2003-04-30) - 395
-
legacy (2003-03-20) - 288a
-
incorporation-company (2003-02-13) - NEWINC