-
MACKS SOLICITORS LIMITED - 4 Woodlands Road, Middlesbrough, TS1 3BE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04609487
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Woodlands Road
- Middlesbrough
- TS1 3BE 4 Woodlands Road, Middlesbrough, TS1 3BE UK
Management
- Geschäftsführung
- DOUGLAS, Neil Andrew
- GRAINGER, Sean Peter
- WATSON, Eric James
- WATSON, James
- WATSON, Joseph John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.12.2002
- Alter der Firma 2002-12-05 21 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Watson Woodhouse Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MACKS SOLICITORS
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-05
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-19
- Letzte Einreichung: 2020-12-05
-
MACKS SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- MACKS SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04609487. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.12.2002 registriert. MACKS SOLICITORS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MACKS SOLICITORS ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 05.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 4 Woodlands Road erreicht werden.
Jetzt sichern MACKS SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Macks Solicitors Limited - 4 Woodlands Road, Middlesbrough, TS1 3BE, Grossbritannien
- 2002-12-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MACKS SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-28) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-31) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
reregistration-private-unlimited-to-private-limited-company (2018-01-10) - RR06
-
resolution (2018-01-10) - RESOLUTIONS
-
re-registration-memorandum-articles (2018-01-10) - MAR
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-08-16) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-11) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-18) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-09-18) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-18) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-18) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-18) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-18) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-17) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-09-18) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-12-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-09) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-09-05) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2011-09-05) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-06) - AR01
-
statement-of-companys-objects (2010-03-12) - CC04
-
resolution (2010-03-12) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-05) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-04-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-01-05) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-01-23) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-12-29) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-14) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-12-10) - 363s
-
legacy (2004-07-01) - 288a
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-12-17) - 363s
-
resolution (2003-05-16) - RESOLUTIONS
-
legacy (2003-04-14) - 225
-
legacy (2003-01-17) - 395
-
legacy (2003-01-09) - 288b
-
legacy (2003-01-09) - 288a
keyboard_arrow_right 2002
-
incorporation-company (2002-12-05) - NEWINC