-
SODA PICTURES LIMITED - 24 Conduit Place, London, W2 1EP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04594425
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 24 Conduit Place
- London
- W2 1EP 24 Conduit Place, London, W2 1EP UK
Management
- Geschäftsführung
- FLETCHER, Edward Mark
- GABEREAU, Eve Jeanne
- WHITE, Cameron William Douglas
- Prokuristen
- GABEREAU, Eve
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.11.2002
- Alter der Firma 2002-11-19 21 Jahre
- SIC/NACE
- 59131
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Thunderbird Films Inc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-12-31
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-12-03
- Letzte Einreichung: 2016-11-19
-
SODA PICTURES LIMITED Firmenbeschreibung
- SODA PICTURES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04594425. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.11.2002 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59131" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2015 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 24 Conduit Place erreicht werden.
Jetzt sichern SODA PICTURES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Soda Pictures Limited - 24 Conduit Place, London, W2 1EP, Grossbritannien
- 2002-11-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SODA PICTURES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-10) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-06-21) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-27) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-06-27) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-07-09) - NDISC
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-06-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-21) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2017-04-19) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-04-19) - 600
-
resolution (2017-04-19) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-10) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-09-02) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-23) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-11) - MR01
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2016-11-01) - RP04AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company (2015-12-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-15) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-18) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-16) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-11-21) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-02-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-03-13) - 363a
-
legacy (2008-04-04) - 363a
-
legacy (2008-03-11) - 288c
-
legacy (2008-12-09) - 288c
-
legacy (2008-12-10) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-09-22) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-12-21) - 395
-
legacy (2007-12-17) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-09-05) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-12-21) - 363s
-
legacy (2005-03-16) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-09-29) - 395
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2004-09-15) - AA
-
legacy (2004-05-19) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-10-03) - 287
-
legacy (2003-10-03) - 225
keyboard_arrow_right 2002
-
incorporation-company (2002-11-19) - NEWINC