-
DESIGN HIVE LIMITED - 30, St. Georges Road, Badshot Lea, Farnham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04566184
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 30
- St. Georges Road
- Badshot Lea
- Farnham
- GU9 9LX
- England 30, St. Georges Road, Badshot Lea, Farnham, GU9 9LX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HUXFORD, Richard
- HUXFORD, Sarah Alexandra
- WAREHAM, Philip Llewelyn
- Prokuristen
- HUXFORD, Sarah Alexandra
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.10.2002
- Alter der Firma 2002-10-17 21 Jahre
- SIC/NACE
- 74100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard Huxford
- Mrs Sarah Alexandra Huxford
- Mr Richard Huxford
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-10-17
-
DESIGN HIVE LIMITED Firmenbeschreibung
- DESIGN HIVE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04566184. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.10.2002 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 30 erreicht werden.
Jetzt sichern DESIGN HIVE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Design Hive Limited - 30, St. Georges Road, Badshot Lea, Farnham, Grossbritannien
- 2002-10-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DESIGN HIVE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-07-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-26) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-24) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-05-05) - SH03
-
resolution (2016-04-14) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-04-01) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-01) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-04-01) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-12) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-07) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-24) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-22) - 363a
-
legacy (2008-10-22) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-11) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-05) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-08-22) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-01-02) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-06-07) - 395
-
legacy (2006-06-29) - 287
-
legacy (2006-05-24) - 288c
-
legacy (2006-11-01) - 363s
-
legacy (2006-07-25) - 288c
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-11-01) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-07-07) - AA
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-10-25) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-07-07) - AA
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-10-29) - 363s
-
legacy (2003-06-11) - 225
-
legacy (2003-06-11) - 88(2)R
-
legacy (2003-06-11) - 288a
-
legacy (2003-01-30) - 287
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-10-25) - 288b
-
incorporation-company (2002-10-17) - NEWINC