-
DENOVA INTERNATIONAL LIMITED - 30, St. Paul's Square, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04477155
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 30
- St. Paul's Square
- Birmingham
- West Midlands
- B3 1QZ 30, St. Paul's Square, Birmingham, West Midlands, B3 1QZ UK
Management
- Geschäftsführung
- DALE, Jonathan
- DALE, Susan Mary
- Prokuristen
- DALE, Jonathan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.07.2002
- Gelöscht am:
- 2020-08-26
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jonathan Dale
- Mrs Susan Mary Dale
- Mr Jonathan Dale
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2014-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-07-04
-
DENOVA INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- DENOVA INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04477155. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.07.2002 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.07.2013.Die Firma kann schriftlich über 30 erreicht werden.
Jetzt sichern DENOVA INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Denova International Limited - 30, St. Paul's Square, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DENOVA INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-08-26) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-05-26) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-08-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-15) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-06-11) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-06-11) - LIQ01
-
resolution (2018-06-11) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-01) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-29) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-29) - AA
-
termination-director-company-with-name (2011-03-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-06) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2009-09-21) - AA
-
legacy (2009-07-07) - 363a
-
legacy (2009-07-06) - 288a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-12) - 288c
-
legacy (2008-11-12) - 287
-
legacy (2008-07-04) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-05-29) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-04) - 363a
-
legacy (2007-07-03) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-05-16) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-07-13) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-04-21) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2005-05-18) - AA
-
legacy (2005-10-28) - 288b
-
legacy (2005-07-13) - 363s
-
legacy (2005-11-09) - 288a
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-07-08) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2004-05-04) - AA
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-07-13) - 363s
-
legacy (2003-05-10) - 225
-
legacy (2003-04-30) - 287
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-07-19) - 287
-
legacy (2002-07-18) - 288a
-
legacy (2002-07-18) - 287
-
legacy (2002-07-12) - 288b
-
incorporation-company (2002-07-04) - NEWINC