-
SANDWELL CASTINGS LIMITED - MAZARS LLP, 45 Church Street, Birmingham, B3 2RT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04253363
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- MAZARS LLP
- 45 Church Street
- Birmingham
- B3 2RT MAZARS LLP, 45 Church Street, Birmingham, B3 2RT UK
Management
- Geschäftsführung
- ALLPORT, Martin Leslie
- BLACKMORE, David Anthony
- GREEN, Peter Richard
- LLOYD, Steven Richard
- Prokuristen
- BLACKMORE, David Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.07.2001
- Gelöscht am:
- 2018-12-11
- SIC/NACE
- 2742
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- GREEN YANKEE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2005-08-31
- Letzte Einreichung: 2003-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2003-07-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-07-31
- Letzte Einreichung:
-
SANDWELL CASTINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- SANDWELL CASTINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04253363. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.07.2001 registriert. SANDWELL CASTINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GREEN YANKEE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "2742" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2003 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.07.2003.Die Firma kann schriftlich über Mazars Llp erreicht werden.
Jetzt sichern SANDWELL CASTINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sandwell Castings Limited - MAZARS LLP, 45 Church Street, Birmingham, B3 2RT, Grossbritannien
- 2001-07-17
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SANDWELL CASTINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
order-of-court-restoration-previously-creditors-voluntary-liquidation (2020-07-02) - REST-CVL
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-09-25) - GAZ1
-
gazette-dissolved-compulsory (2018-12-11) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2015
-
restoration-order-of-court (2015-08-19) - AC92
keyboard_arrow_right 2011
-
gazette-dissolved-liquidation (2011-09-29) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2011-06-29) - 4.68
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2011-06-29) - 4.72
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2011-02-07) - 4.68
keyboard_arrow_right 2010
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-10-07) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2010-08-18) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2010-02-17) - 4.68
keyboard_arrow_right 2009
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2009-08-07) - 4.68
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2009-02-16) - 4.68
keyboard_arrow_right 2008
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments (2008-02-11) - 4.68
-
legacy (2008-06-05) - 405(2)
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2008-06-05) - 3.6
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2008-08-28) - 4.68
keyboard_arrow_right 2007
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments (2007-09-05) - 4.68
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments (2007-07-24) - 3.6
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-02-24) - 287
-
resolution (2006-08-09) - RESOLUTIONS
-
legacy (2006-08-04) - 287
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2006-08-02) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2006-08-02) - 600
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments (2006-06-30) - 3.6
keyboard_arrow_right 2005
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments (2005-07-14) - 3.6
keyboard_arrow_right 2004
-
liquidation-receiver-administrative-receivers-report (2004-08-28) - 3.10
-
legacy (2004-06-23) - 287
-
legacy (2004-06-17) - 405(1)
-
accounts-with-accounts-type-full (2004-03-09) - AA
-
auditors-resignation-company (2004-01-09) - AUD
-
miscellaneous (2004-08-28) - MISC
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-07-25) - 395
-
accounts-with-accounts-type-full (2003-04-13) - AA
-
legacy (2003-08-20) - 363s
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-09-02) - 363s
-
legacy (2002-05-17) - 225
keyboard_arrow_right 2001
-
legacy (2001-11-28) - 288b
-
certificate-change-of-name-company (2001-11-26) - CERTNM
-
resolution (2001-11-28) - RESOLUTIONS
-
legacy (2001-11-28) - 88(2)R
-
legacy (2001-11-28) - 287
-
legacy (2001-12-13) - 395
-
legacy (2001-11-28) - 288a
-
incorporation-company (2001-07-17) - NEWINC