-
DS BUSINESS SERVICES LTD - 9 Pennyroyal, Fleet, Hampshire, GU51 5BH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 03900769
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9 Pennyroyal
- Fleet
- Hampshire
- GU51 5BH 9 Pennyroyal, Fleet, Hampshire, GU51 5BH UK
Management
- Geschäftsführung
- SPROT, David
- Prokuristen
- BARANDIARAN-SPROT, Cecilia Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.12.1999
- Gelöscht am:
- 2021-05-25
- SIC/NACE
- 69201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Cecilia Elizabeth Barandiaran-Sprot
- Mr David Sprot
- Mr David Sprot
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-12-20
-
DS BUSINESS SERVICES LTD Firmenbeschreibung
- DS BUSINESS SERVICES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 03900769. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.12.1999 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69201" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 9 Pennyroyal erreicht werden.
Jetzt sichern DS BUSINESS SERVICES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ds Business Services Ltd - 9 Pennyroyal, Fleet, Hampshire, GU51 5BH, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DS BUSINESS SERVICES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-03-09) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-02-24) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-11-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-06-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-06) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-01-06) - CH03
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-01) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-01-05) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-12-08) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-12-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-09-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-12-30) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2011-02-13) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-13) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-12-07) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2010-01-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-12) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-12) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-02-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-10-23) - AA
-
legacy (2008-01-22) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-12-27) - AA
-
legacy (2007-01-12) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-08-29) - AA
-
legacy (2006-02-16) - 363s
-
legacy (2006-02-16) - 288a
-
legacy (2006-01-16) - 288a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-01-06) - AA
-
legacy (2006-01-06) - 288b
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-01-10) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-01-09) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2004-01-13) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2004-11-26) - AA
-
legacy (2004-11-10) - 287
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-02-08) - 363s
keyboard_arrow_right 2002
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2002-11-29) - AA
-
legacy (2002-01-04) - 363s
keyboard_arrow_right 2001
-
accounts-with-accounts-type-full (2001-06-14) - AA
-
legacy (2001-01-29) - 363s
keyboard_arrow_right 2000
-
legacy (2000-04-21) - 225
-
legacy (2000-01-18) - 287
-
legacy (2000-01-18) - 288a
-
legacy (2000-01-11) - 288a
keyboard_arrow_right 1999
-
incorporation-company (1999-12-29) - NEWINC