-
-
POSITIVE MENTAL HEALTH LIMITED - Cannon Green 3rd Floor, 27 Bush Lane, London, EC4R 0AA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08905035
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cannon Green 3rd Floor
- 27 Bush Lane
- London
- EC4R 0AA
- England Cannon Green 3rd Floor, 27 Bush Lane, London, EC4R 0AA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SPRUCE, Olivia Helen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-20 11 Jahre
- SIC/NACE
- 78109, 78200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gary Peter Ashworth
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- POSITIVE HEALTHCARE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-01
- Letzte Einreichung: 2020-02-18
-
POSITIVE MENTAL HEALTH LIMITED Firmenbeschreibung
- POSITIVE MENTAL HEALTH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08905035. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.02.2014 registriert. POSITIVE MENTAL HEALTH LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen POSITIVE HEALTHCARE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Cannon Green 3Rd Floor erreicht werden.
Jetzt sichern POSITIVE MENTAL HEALTH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Positive Mental Health Limited - Cannon Green 3rd Floor, 27 Bush Lane, London, EC4R 0AA, Grossbritannien
- 2014-02-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu POSITIVE MENTAL HEALTH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-18) - CS01
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-09-29) - SH02
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-05-22) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-21) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-21) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-27) - AA
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-01-08) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
legacy (2018-01-05) - AGREEMENT2
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-18) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-13) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-18) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2018-12-11) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-09-29) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-08-08) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-06) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-29) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-04-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-28) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-03-23) - AA01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-05-13) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-30) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-30) - AR01
-
resolution (2015-03-31) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-31) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-03-31) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-06-03) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-06) - TM01
-
change-of-name-notice (2015-11-09) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-11-09) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-25) - MR01
-
incorporation-company (2014-02-20) - NEWINC