-
-
QUANTUM MOTORSPORTS LIMITED - 43-47 Arundel Gardens, Notting Hill, London, W11 2LP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08554369
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 43-47 Arundel Gardens
- Notting Hill
- London
- W11 2LP
- United Kingdom 43-47 Arundel Gardens, Notting Hill, London, W11 2LP, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- IJAZ, Mansoor
- PATHUEL, Jan
- Prokuristen
- AYNILIAN, Nicholas Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.06.2013
- Gelöscht am:
- 2020-11-17
- SIC/NACE
- 93199
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr. Musawer Mansoor Ijaz
- Dr. Jan Pathuel
- Dr. Jan Pathuel
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- -
- -
- Ehemalige Namen
- INFINITY RACING PARTNERS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-03-03
- Letzte Einreichung: 2016-06-30
-
QUANTUM MOTORSPORTS LIMITED Firmenbeschreibung
- 43-47 Arundel Gardens erreicht werden.
Jetzt sichern QUANTUM MOTORSPORTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Quantum Motorsports Limited - 43-47 Arundel Gardens, Notting Hill, London, W11 2LP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu QUANTUM MOTORSPORTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-compulsory (2020-11-17) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-02) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-02-03) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-03) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-03) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-14) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-11-21) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-12-09) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-01) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2016-11-22) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-11-30) - DISS40
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-11) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-11) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-06-03) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2013-10-09) - CERTNM