-
-
RAYNES PARK HEALTH LIMITED - BM ADVISORY LLP, 82 St. John Street, London, EC1M 4JN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07402316
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- BM ADVISORY LLP
- 82 St. John Street
- London
- EC1M 4JN BM ADVISORY LLP, 82 St. John Street, London, EC1M 4JN UK
Management
- Geschäftsführung
- ALA, Azhar, Dr
- DE WILDE, Stephen James, Dr
- LANE, Michael Ronald, Dr
- MOLONY, Conor John, Dr
- ROBERTS, Judith Alison, Dr
- ROHDE, Simon Peter, Dr
- SMITH, Penelope Elaine, Dr
- VEIRAS, Maria Bernadette, Dr
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.10.2010
- Gelöscht am:
- 2018-05-13
- SIC/NACE
- 86210
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
-
RAYNES PARK HEALTH LIMITED Firmenbeschreibung
- RAYNES PARK HEALTH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07402316. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.10.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86210" registriert. Das Unternehmen hat 8 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2015 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Bm Advisory Llp erreicht werden.
Jetzt sichern RAYNES PARK HEALTH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Raynes Park Health Limited - BM ADVISORY LLP, 82 St. John Street, London, EC1M 4JN, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RAYNES PARK HEALTH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2018
-
gazette-dissolved-liquidation (2018-05-13) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2018-02-13) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2017
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2017-10-30) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-disclaimer-notice (2016-11-07) - F10.2
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-26) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-10-24) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-10-24) - 600
-
resolution (2016-10-24) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2016-05-05) - MA
-
resolution (2016-05-05) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-11-02) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-04) - AR01
-
resolution (2015-11-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-30) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-07-10) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-06-20) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-20) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-05-14) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-05-14) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-14) - AP01
-
resolution (2013-04-09) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-04-09) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-05-09) - AP01
-
resolution (2013-04-24) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-05-14) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2013-05-14) - SH08
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-06) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-11-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-07-05) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-12-09) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-12-09) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-02) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-05-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-10-11) - NEWINC