-
JMP CONSULTANTS LIMITED - 3rd, Floor 5 Old Bailey, London, EC4M 7BA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08158942
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd
- Floor 5 Old Bailey
- London
- EC4M 7BA
- England 3rd, Floor 5 Old Bailey, London, EC4M 7BA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HIGHAM, Steve John
- LEWIS, Timothy
- MCNAUGHTON, Andrew James
- Prokuristen
- MORGAN, Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.07.2012
- Gelöscht am:
- 2020-03-17
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Systra Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- VOLVERE CLAIMS SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2015-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
-
JMP CONSULTANTS LIMITED Firmenbeschreibung
- JMP CONSULTANTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08158942. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 27.07.2012 registriert. JMP CONSULTANTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VOLVERE CLAIMS SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 3Rd erreicht werden.
Jetzt sichern JMP CONSULTANTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jmp Consultants Limited - 3rd, Floor 5 Old Bailey, London, EC4M 7BA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JMP CONSULTANTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-03-17) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-22) - TM01
-
gazette-notice-voluntary (2019-12-31) - GAZ1(A)
-
legacy (2019-12-20) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-12-20) - SH19
-
legacy (2019-12-20) - SH20
-
dissolution-application-strike-off-company (2019-12-23) - DS01
-
resolution (2019-12-20) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-01-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-19) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-06-14) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-02) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-11-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-11-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-31) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-01-11) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-01-10) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-06) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-03) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-01-03) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-01-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-08) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-02-02) - AP03
-
auditors-resignation-company (2016-01-04) - AUD
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-27) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-27) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-12-18) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-09-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-18) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-12-18) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-25) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-04-09) - SH08
-
capital-allotment-shares (2014-04-09) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-06-20) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-21) - AR01
-
memorandum-articles (2014-04-09) - MEM/ARTS
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-20) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-06-03) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2013-05-17) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2013-05-15) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-27) - NEWINC