-
WENTWORTH MILLER LIMITED - Gregs Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07405421
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Gregs Building
- 1 Booth Street
- Manchester
- M2 4DU Gregs Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU UK
Management
- Geschäftsführung
- HAMPSON, Paul Bernard
- HUGHES, John William
- Prokuristen
- HUGHES, John William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.10.2010
- Alter der Firma 2010-10-13 13 Jahre
- SIC/NACE
- 82110
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2016-12-31
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-13
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2016-10-27
- Letzte Einreichung:
-
WENTWORTH MILLER LIMITED Firmenbeschreibung
- WENTWORTH MILLER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07405421. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.10.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 13.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Gregs Building erreicht werden.
Jetzt sichern WENTWORTH MILLER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wentworth Miller Limited - Gregs Building, 1 Booth Street, Manchester, M2 4DU, Grossbritannien
- 2010-10-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WENTWORTH MILLER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-release-of-liquidator-by-secretary-of-state (2020-07-16) - LIQ12
-
liquidation-miscellaneous (2020-07-22) - LIQ MISC
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-02-25) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-02-26) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-01-12) - 600
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2018-01-02) - AM22
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-26) - AD01
-
liquidation-in-administration-progress-report (2017-08-04) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2017-07-16) - AM19
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2017-02-22) - 2.23B
-
liquidation-in-administration-progress-report-with-brought-down-date (2017-02-09) - 2.24B
keyboard_arrow_right 2016
-
liquidation-in-administration-proposals (2016-09-01) - 2.17B
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2016-09-14) - 2.23B
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-09-01) - 2.16B
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-19) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2016-07-16) - 2.12B
keyboard_arrow_right 2015
-
legacy (2015-04-27) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2015-05-15) - SH19
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-26) - AR01
-
resolution (2015-04-27) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-26) - AA
-
legacy (2015-04-27) - CAP-SS
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-04-22) - SH08
-
capital-allotment-shares (2015-04-22) - SH01
-
resolution (2015-04-22) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-04) - AR01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2014-05-07) - AAMD
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-04-05) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-04-05) - AD01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-04-05) - CH03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-09-19) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-16) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-11-08) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-12-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-09-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-22) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-12-22) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-10-13) - NEWINC