-
ARMFIELD CONSTRUCTION LIMITED - 100 St. James Road, Northampton, NN5 5LF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07019630
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 100 St. James Road
- Northampton
- NN5 5LF 100 St. James Road, Northampton, NN5 5LF UK
Management
- Geschäftsführung
- POWDRELL, Peter
- WHAPHAM, James William Alexander
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.09.2009
- Alter der Firma 2009-09-15 14 Jahre
- SIC/NACE
- 41201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Peter Powdrell
- Mr Peter Powdrell
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- ARMFIELD INTERIORS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-29
- Letzte Einreichung: 2020-09-15
-
ARMFIELD CONSTRUCTION LIMITED Firmenbeschreibung
- ARMFIELD CONSTRUCTION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07019630. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.09.2009 registriert. ARMFIELD CONSTRUCTION LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ARMFIELD INTERIORS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41201" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 100 St. James Road erreicht werden.
Jetzt sichern ARMFIELD CONSTRUCTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Armfield Construction Limited - 100 St. James Road, Northampton, NN5 5LF, Grossbritannien
- 2009-09-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ARMFIELD CONSTRUCTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-03-26) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-27) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-30) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-30) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-27) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-13) - PSC04
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-26) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-04) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-30) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-14) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-04) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-04) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-06) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-07-18) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2013-07-03) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-07-03) - CONNOT
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-07-03) - SH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-10-03) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-07-04) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2011-06-13) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-06) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-07-13) - AP01
-
capital-allotment-shares (2010-06-02) - SH01
-
capital-allotment-shares (2010-05-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2009
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-29) - CH01
-
legacy (2009-09-17) - 288b
-
incorporation-company (2009-09-15) - NEWINC